military collection v. war of the revolution box no ...military collection v. war of the revolution...

34
MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 17801781 Account of John Haywood, secretary Journal Correspondence 2 Commissary Correspondence, 17791781 3 Commissary Correspondence, 17821783 Orders to the Commissary General Commissary General's Letter Book 4 British and Loyalist Papers "A British Orderly Book, 17801781" (sometimes called the Cornwallis Orderly Book) British Soldiers' Account Book, 17761778 "Observations on the War in Carolina" by Colonel Robert Gray, officer of provincial troops Loyalist discharge, 1783 [MISSING] 5 Miscellaneous Papers, 17761789 1776court martial of Captain Aaron Hill 1776depositions on treason of James Childs 1777Recruiting Instructions 1778depositions on James Davis' assault on Colonel Cheriol 1778Pay abstract of Captain Samuel Ash’s Troop of Light Dragoons. 1778Major Dixon's criticism of officers' attitudes and list of garrison court martial sentences 1778court of inquiry into certain enlistments: Abraham Smith, Jacob Ford, John Row, Josiah Lasiter, Benjamin Smith 1778courtmartial of Captain Nicholas Edmonds 17781779depositions in inquiry on drafting of troops in Anson County 1779regimental court martial of Francis Madcalf 1779drum head court martial of George Gilbert 1779Tory recruiting in Wilkes County

Upload: others

Post on 20-Mar-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Box No.  Contents  1    Board of War, 1780‐1781       Account of John Haywood, secretary       Journal       Correspondence  2    Commissary Correspondence, 1779‐1781  3    Commissary Correspondence, 1782‐1783       Orders to the Commissary General       Commissary General's Letter Book  4    British and Loyalist Papers 

"A British Orderly Book, 1780‐1781" (sometimes called the Cornwallis Orderly Book) 

British Soldiers' Account Book, 1776‐1778        "Observations on the War in Carolina" by Colonel 

Robert Gray, officer of provincial troops       Loyalist discharge, 1783 [MISSING]  5    Miscellaneous Papers, 1776‐1789       1776‐court martial of Captain Aaron Hill       1776‐depositions on treason of James Childs       1777‐Recruiting Instructions       1778‐depositions on James Davis' assault on Colonel 

Cheriol       1778‐Pay abstract of Captain Samuel Ash’s Troop of  

Light Dragoons.       1778‐Major Dixon's criticism of officers' attitudes 

and list of garrison court martial sentences       1778‐court of inquiry into certain enlistments: 

Abraham Smith, Jacob Ford, John Row, Josiah Lasiter, Benjamin Smith 

      1778‐court‐martial of Captain Nicholas Edmonds       1778‐1779‐depositions in inquiry on drafting of 

troops in Anson County       1779‐regimental court martial of Francis Madcalf       1779‐drum head court martial of George Gilbert       1779‐Tory recruiting in Wilkes County 

 

Page 2: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                

  

 Box No.  Contents  5 (cont.)1779‐depositions on privateers lying off Knotts Is. 

[1779]John Williams' account of efforts to exchange prisoners in New York under a flag of truce 

1780‐prisoner of war's parole from the British     1780‐prisoners held in the Bahama Islands to seek 

exchange in North Carolina 1780‐inquest on the shooting of Curlen Woodard, believed to be a deserter 

    1780‐trial of Charles Robinson, Richmond County     1780‐court martial of Colonel Joseph Spruill, Tyrrell  

County     1781‐court of reference in dispute between Captain 

Hearndon and Captain Lanor     1781‐General Washington's regulations on uniforms     1781‐Request for Provisions [August 7, 1781]     1782‐Wilkes County list of officers of the court martial     1782‐inquiry into the shooting of Robert Grissom by Lt. 

Steven Shackleford, Onslow County     1782‐Board of Officers meeting on continuation in service     1782‐Nash County court martial: list of exemptions from 

service     1783‐Inspection return, lst N.C. Regiment     1789‐deposition on public stores destroyed by the enemy 

at Wilmington in 1781     Declarations for United States pensions: David Bagwell, 

John Wyatt Non‐Revolutionary War fragment of an unidentified   

newspaper [mentions casualties of the Battle of Bunker Hill].  6  Miscellaneous Papers  

"An original Orderly Book of a Portion of the American Army, during the War of the Revolution, covering a period from February 7, 1777, to August 13, 1777, at various points, viz.: Hadril's Point, Wilmington, Halifax, Roanoke, Georgetown, Philadelphia, Trenton." MAY NOT BE COPIED. 

Page 3: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                

[ORIGINAL IN POSSESSION OF THE JOHN HAY LIBRARY, BROWN UNIVERSITY] 

  

 Box No.  Contents  6 (cont.) 

Plan du Combat du 16 Aout 1780 . . .; and Relation du Combat pour l’intelligence du plan ci‐contre. [Previously accessioned as Map Collection, M.C. 21‐G]. 

     Jeffrey Coltrane Jr. Collection        Contains pamphlet titled, North Carolina Troops in  

the Continental Line, A Register of Officers, with Dates of Commissions, Made up under Direction of the Secretary of State from Records in His Office, October, 1884. 

 Box No.  Contents  7 – 14  Declaration of Service to Accompany U.S. Pension  

Applications    Negative photostats from county court minutes and xerox copies  

from county miscellaneous papers of declarations of  service by Revolutionary War veterans intending to apply  for pensions, under various acts of the U.S. Congress.  The originals from which these copies were made were  searched by Betty Camin.  

  Arrangement is alphabetical by the name of the veteran. The  86 files marked with an asterisk(*) in the following  list represent declarations for which no files exist,  presumably in the Revolutionary War Pension  Applications at the National Archives, Washington, D.C.  

List prepared by Betty Camin (as a volunteer service to the North Carolina State Archives)  DEPONENT        DATE  COUNTY 

Page 4: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                  Adams, Henry      1810  Franklin Adams, James     1832  Wake Adams, Jeremiah    1791 Lincoln Adams, Jeremiah    1827  Mecklenburg Agle (Eagle), Phillip  1819  Rowan Allen, Bartlett    1832  Wake Allen, Benjamin    1821  Pasquotank Allen, Samuel      1832  Orange Allison, James      1832  Orange Alphin, William    1827 Duplin Ashe, John Baptista    1783  T & C Atkinson, James    1825  Stokes Avery, Robert      1824  Pasquotank Babb, Christopher    1832  Wake Bachelor, Susanna    1845  Orange Baily, Manoah     1820  Stokes Baily, Stephen     1819  Rowan Balthrop, Augustine    1842  Warren Banks, Joseph      1824  Pasquotank Banks, Peter      1832  Craven  

 Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Bankston, Andrew    1834  Rutherford Banner, Ephraim, dec'd  1838  Stokes Barham, Hartwell    1846  Stokes Barnet, Peter      1820  Person Barr, Isaac      1820  Stokes Barrington, Joseph B.  1828  Edgecombe Barthalomew, John    1824  Franklin Bartlett, Hasten    1830  Person Bates, Isaac      1798  Buncombe Bennett, Benjamin Clifton1841 Warren  Bennett, John      1832 Rutherford Berry, John       1818 Camden‐Perquimans Bilbury, John      1816  Columbus Black, Martin      1820  Craven 

Page 5: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Blalock, David      1834 Rutherford Bledsoe, Jacob     1828  Orange Blum, John Henry    1822  Stokes Bone, Archibald    1820 Cumberland Boone, Elisha      1821  Wake Bower, John B.      1824  Orange Bradford, Susanah    1849  Caldwell Bradley, George W.(dec'd)1832 Rutherford Bramble, William (Hacket)1820 Cumberland Branch, Burrill   1832  Duplin Brandon, Thomas    1801  Buncombe Brooks, William    1833  Rutherford Broughton, John    1832  Caswell Brown, James      1832  Wake Brown, William      1841  Warren Brown, William      1821 Perquimans Browning, Levi     1832  Halifax Bryant, Jesse      1832  Wake Bullin, Isaac         1825‐1846  Stokes Cameron, John (Jane) 1848  Cumberland Campbell, Capt. James(dec'd)1820  Cumberland Campbell, James    1821 Stokes Camperlane, Jacob, Capt.  1798  Stokes Cannon Furney (dec'd)  1853  Craven Capps, William      1828  Johnston  

 Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Chappel[e], Samuel    1825  Granville Chatham, John      1820  Person Carlisle, David (dec'd) 1823  Chatham Carmack, John     1832  Guilford Carmichael, Duncan    1821  Stokes Carpenter, Benjamin(dec'd)1838 Wake Carrol, John      1852  Chatham Carter, Henry      1828  Stokes Carter, John      1820  Craven Carter, James      1832  Orange 

Page 6: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Carter, Landon      1825  Stokes Carter, Zachariah    1832  Duplin Chapman, William    1820  Rowan Cheek, James      1832  Orange Church, William    1836  Davidson Clarey, John      ‐‐  Warren Clements, Benjamin    1858  Stokes Clements, Cornelius    1834 Rutherford Clifton, William    1838  Lincoln Cobb, David      1838  Lincoln Cock, Charles      1832  Caswell Collins, Jeremiah    1826  Stokes Collins, Matthew    1790  T & C Cook, Edward      1832 Rutherford Coulter, Martin    1853 Lincoln Cowan, Joseph      1826  Haywood Cox, James      1847  Stokes Cox, John        1820  Craven Cox, Joshua (dec'd)    1837  Stokes Craddock, John (dec'd)  1837  Craven Crump, Conrad      1844  Burke Cuthbertson, Rachel [William] 

  1844  Burke Dallay, John      1833  Orange Dalton, Thomas      1834 Rutherford Dalton, William    1830 Rutherford Dameron, George    1824  Lincoln Dance, Etheldred    1820 Nash Daniel, Christopher    1832  Orange Davis, Cyrus      1820  Granville 

 Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Davis, Cyrus, Sr.    1828  Granville Davis, John, Sr.    1830 Rutherford Davis, Richard     1828  Orange Davis, Samuel      1820  Rowan Davis. Samuel      1820  Stokes Davis, Simon      1835 Rutherford 

Page 7: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Davis, William     1834 Pasquotank Dawson, Levi, Co. (dec'd)1838  Craven Denton, John      1827 Rutherford DePriest, William    1832 Rutherford Devane, James      1832 New Hanover Devaney, Aaron      1834 Rutherford Dicken, William    1832  Halifax Dickins (ens), Thomas 1823  Chatham Dickey,   Anthony    1832 Rutherford Dickin,   John      1823  Chatham Dickson, Joseph    1821  Lincoln Dill, John      1832  Caswell Dishon, Lewis (dec'd)  1844  Chowan Dobbins, James      1832 Rutherford Dodd, Robert      1820  Wake Dollar, Jonathan    1833  Orange Downey, Patrick    1832 Rutherford Drury, Henry (Pen.)    1820 Nash Dubberly, Sacker    1832  Craven Dudley, George      1823  Chatham Duhron, George      1821  Lincoln Duncan, George      1821  Person Dunn, George      1818  Rowan Durden, Miles, P.    1823  Person Eason, Jacob      1820 New Hanover East, Isham (dec'd)    1843  Stokes Eaton, William     1821  Stokes Edwards, John (dec'd) 1834  Surry Edwards, Pumfret    1821  Wake Elland, John      1832  Orange Ellis, Michael      1832  Orange Ellison, Charles    1802  Rowan Ellison, John      1832 Rutherford Epperson, William (dec'd)1838  Stokes 

 Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Evans, Reuben     1830  Wake Fagg, Joseph      1820 Warren 

Page 8: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Falkener, Hardy (dec'd)  1838  Warren Farwell, James     1820  Lincoln Faucett, Robert    1818  Rowan Fennell. Maurice    1823  Sampson Findley, John      1832  Guilford Fink, David        1818 Cabarrus and Rowan Flinn, John (dec'd)    1821  Stokes Folk, William      1819  Rowan Foster, Edmund      1827 Rutherford Francis, Micajah    1831  Stokes Franch, Sifford   1832 Rutherford Frazer, Lowell      1834  Stokes Frazer, Thomas      1820  Johnston Gattin, Jesse      1821  Randolph Gattis, Alexander    1832  Orange Gerock, Samuel      1829  Craven Gibbs, John      1844  Burke Glandon, Major      1827  ]Nash Gordon, Charles C.    1826  Guilford Gordon, Solomon    1824  Warren Gouch, Robin      1832  Wake Graham, James (dec'd)  1834  Rowan Graham, William    1832 Rutherford Green, George     1832  Halifax Green, John      1832  Wake Gregory, Abraham    1820  Person Gregory, John      1832  Craven Gurott, John      1832  Person Gwaltney, Nathan    1820  Lincoln Hamilton, Thomas    1821  Nash Hampton, Stephen    1852  Stokes Hargis, Thomas      1832  Person Harper,  Jethro    1832  Halifax Harper, John      1832  Halifax Harris,  Edward       1821  Johnston Harris,  Jesse      1821  Johnston Harris,  John      1833 Pasquotank Harris,  Robin (dec'd)  1842  Warren                                     

 

Page 9: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Harrison, Jesse    1820‐1823 Rowan‐Davidson Harrison, John     1818  Franklin Harrison, William    1824  Franklin Hart, James      1832  Orange Harvy, Robert      1832 Rutherford Harwood, James      1832  Wake Hawkins, Ephraim    1832  Person Hayes, Thomas      1826  Granville Haymore, Britain J.    1824  Davidson Hays, David      1844  Burke Hewett, Ebenezer    1821  Brunswick Hickman, Jacob      1801  Guilford Hickman, Richard    1821  Guilford Hicks, Micajah     1829  Orange Hill, Reuben      1832 Rutherford Hill, Robert      1852  Stokes Hobbs, John      1821  Orange Hobdy, William      1818 New Hanover Hofstatler, George    1792  Lincoln Holland, Williams    1832 Rutherford Hollowell, Samuel    1786 Pasquotank Holt, George      1832  Orange Hood, Charles      1820  Person Hood, Thomas     1820  Person Hooper, William (dec'd)  1838  Stokes Hopkins, William    1832  Orange Hopson, Benjamin    1841  Wake Horner, Thomas      1832  Orange Houser, Goerge (dec'd)  1838  Stokes Hudgins, James F.    1845  Warren Hudgins, John      1832  Orange Hughes, John      1832  Orange Hunt, David      1820  Nash Hutchins, Thomas    1832 Rutherford Ipock, Samuel      1832  Craven Irvine, James      1832 Rutherford Ives, John P.      1832  Craven 

Page 10: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Jackson, Thomas (Dec'd)  1833 Pasquotank Jacobs, Primus     1820 New Hanover James, Elisha      1824  Halifax                                     

 Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Jenkins, John (dec'd)  1840 Rutherford Jenkins, Lewis      1818  Rowan Jinks, Thomas      1832  Wake Johnson, Croford    1820  Warren Johnson, Frederick (dec'd)1840 Rutherford Johnson, Joseph    1820  Chatham Johnson, Thomas    1820  Granville Jones, Edward     1822  Guilford Jones, Elisha      1832  Duplin Jones, James      1820  Craven Jones, Peter (dec'd)  1824‐1837  Warren Jones, William     1849  Caldwell Jordan, Caleb (dec'd)  1834 Perquimans Jordan, Edmond      1833 Northampton Joyner, Matthew    1838  Wake Keaton, William (dec'd)  1833 Pasquotank Keel, Charles (dec'd)  1833 Pasquotank Kidds, John      1829  Lincoln King, David (dec'd)    1842  Warren King, John      1822  Franklin King, Vincent      1832  Wake Koen, John      1833 Pasquotank Land, Ephraim     1821  Stokes Lane, Daniel      1833  Craven Land, Jacob      1821 Perquimans Lard, John      1819  Rowan Laughinghouse, John       1845 Beaufort (Pitt) Lauson, Thomas      1845  Iredell Leathers, Moses    1820  Orange Ledbetter, Richard    1832 Rutherford Lee, John        1832  Halifax 

Page 11: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Lefey (Lefcey), Shadrack  1820  Lincoln Lequire (see Sequire) Lewis, John      1829  Rutherford Lingo, William (dec'd) 1815  Orange Lipscomb, Archibald    1832  Person Lock, James, Sr.    1832  Halifax Lock, John         1820‐1828  Granville Locus, Valentine (dec'd)  1836  Wake                                       Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Logan, Drury (dec'd)  1832‐1835  Rutherford Lomack, William    1821 Cumberland Lomax, William           1819‐1829 Rowan‐Davidson Long, John      1824  Edgecombe Lovell, Josepj      1827  Guilford Low, John (dec'd)    1834 Pasquotank Lucas, William     1832 Rutberford Luther, George      1839  Randolph Luther, Michael    1839  Randolph Lynch, Joshua      1820  Wake Mabry, David      1832  Wake Mahaley, John W.    1832  Stoke Mahue, William      1832 Rutherford Maibe, John (dec'd)    1844  Stokes Mainor, Josiah     1820  Sampson Maples, Marmaduke    1821  Lincoln Marcum, Thomas      1832  Orange Markham, Anthony    1833 Pasquotank Marr, John Sr.      1820  Wake Marshall, Benjamin    1840  Stokes Martin, Absalom    1820  Carteret Martin, Jesse      1824  Gates Martin, Joshua      1820  Guilford Mason, Patrick      1828  Person Massey, John      1831  Haywood 

Page 12: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Masters, Enoch      1832  Craven Mattock, John     1823 Rockingham May, Ludwick      1832  Orange Mays, William     1832  Lincoln McClure, Richard    1832 Rutherford McCullers, Col. Matthew  1839  Wake McDaniel, Arthur (dec'd)  1836  Chatham McFaddin, Alex.    1832 Rutherford McKinney, William    1832 Rutherford Mealer, James (dec'd) 1840  Warren Merritt, Daniel    1832  Sampson Merritt, Shadrach    1832  Halifax Merritt, William    1843  Stokes Metcalf, Danja (dec'd)   1832‐1840  Rutherford Metcalf, Warner    1832 Rutherford                                      Camin’s “Declarations of Service” List (Conti.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Miller, John (dec'd)  1832 Perquimans Mills, Jessie      1832 Rutherford Mills, Naamon     1832  Wake Mitchell, Reuben (dec'd)  1820  Chatham Monday, Jeremiah    1827  Lincoln Moody, Edward         1820‐21?  Ashe Moody, Thomas      1820 Cumberland Mooney, David      1832 Rutherford Mooney, William    1820 Rockingham Morgan, Matthias    1824  Gates Morgan, William    1821  Craven Moring, John      1832  Chatham Morphis, John     1824  Orange Morris, Micajah    1830 Rutherford Mott, Benjamin      1827 New Hanover Mott, Edgerton      1820 New Hanover Neese, Martin     1832  Orange Nelson, Edward      1832  Craven Nelson, Samuel      1832  Orange 

Page 13: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Newby, Francis      1822 Perquimans Newsom, Jacob      1832 Rutherford Newton, Benjamin    1832 Rutherford Nicholsen, Caty    1842  Stokes Norfleet, Nathaniel    1832  Person Nugent, Jacob     1826  Guilford 0’Neal, Cynthia [Patrick]1846 Burke Osborn, Stephen    1830  Davidson Olsborn, Jesse     1821  Wake Osteen, Solomon    1820  Camden Ousby, James      1860  Halifax Ousby, Thomas      1857  Halifax Overton, Samuel    1825 Pasquotank Padgett, John      1832 Rutherford Pafford, William    1826  Stokes Painter, George    1834 Rutherford Palmer, William    1833 Pasquotank Patton, Elizabeth [Capt. Robert]1844 Burke Peace, Samuel, Sr.    1823  Granville Pearce, Jacob (dec'd)  1838  Stokes Perkins, Isaac      1829  Craven                                      Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Perkins, William    1832  Halifax Perkinson, Noel    1823  Guilford Pettiford, Drury    1820  Wake Pettiford, George    1831  Granville Pettiford, Phillip    1820  Granville Pettitt, Henry Sr.    1832 Rutherford Pippet, George      1792  Anson Pool, Robert (dec'd)  1833 Pasquotank Porterfield, John    1832  Orange Powell, George      1832  Halifax Powell, James      1841  Warren Powell, Susannah    1842  Burke Pratt, Zebulon     1826  Chowan 

Page 14: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Prescott, Willoughby  1820  Carteret Prichard, Thomas    1818  Rowan Pullum, Zachariah    1832 Rutherford Ragin, Jesse      1832  Person Raper, Robert      1822  Nash Reason, Stephen (dec'd)  1850  Stokes Reaves, Zachariah    1821 Cumberland Reed, Isaac      1799  Craven Reeves, Frederick    1847  Wake Register, John, Jr.    1832  Sampson Register, John, Sr.    1822  Sampson Reid, Benjamin      1821  Gates Reynolds, John      1822 Rutherford Rhodes, John, Sr.    1833  Wake Rigby, John      1832  Duplin Riggin, Joel      1828  Davidson Rigsby, Jesse      1799  Orange Riley, William      1826  Guilford Ring, Thomas (dec'd)  1846  Stokes Roan, Thomas     1832  Caswell Roberts, Cyrus L. (dec'd)1834 Rockingham Roberts, Martin    1825 Rutherford Robins, Lambert    1821  Orange Rose, Phillip (dec'd)  1834 Rockingham Rose, Thomas      1832  Wake Rowin, Bracey     1832  Wake Runyan, John      1824  Haywood                                      Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Rusher, Jacob      1820  Rowan Russell, James     1820  Craven Sampson, Isaac      1820  Craven Sandeford, Samuel    1832  Wake Sargent, James      1832 Rutherford Scarborough, Samuel, Sr.  1832  Wake Scarlet, Thomas (dec'd)  1836  Orange 

Page 15: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Scott, Isham      1823  Halifax Scott, John      1811  Davidson Searcey, Abner      1824  Granville Searcy, John      1832 Rutherford Sequire, John      1832 Rutherford Shamel, John (dec'd)  1838  Stokes Shaw, Daniel      1810 Cumberland Shaw,  Joseph      1832  Wake Shaw, Michael     1818  Rowan Shelby, John      1783  Sullivan Sherran, John      1832  Wake Shipes, Phillip    1818  Rowan Shute, Thomas (dec'd)  1835  Craven Simmons, William    1818  T & C Skipper, James      1826  Wake Sled, William      1830  Wake Smith, David      1820 Cumberland Smith, Henry      1824  Cabarrus Smith, Isaac      1832  Wake Smith, James      1830  Hertford Smith, Reuben     1832  Orange Smith, Rueben (dec'd) 1839 Rockingham Smith, Thomas      1847  Burke Smith, Thomas      1832 Perquimans Smith, William [see Susanah Bradford]1818 Orange Sneid, John      1818  Orange Squire (see Sequire) Spainhour, Michael    1838  Stokes Spears, John      1848 Cumberland Spelmore (Spelmen), Aaron1820  Craven Spelmore, Asa     1820  Craven Spencer, David      1844  Burke Springfield, Moses    1832  Person                                      Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Springs, Micajah    1820  Sampson 

Page 16: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Stacy, Nancy [Aaron]  1843  Burke Stiles, John      1826  Haywood Stiller, Peter      1831  Rowan Strader, John      1832  Orange Stratton, William    1820 Rockingham Strayhorn, William    1832  Orange Stripe, Samuel (dec'd) 1842  Orange Stroud, Delilah (dec'd)  1842  Orange Stutts, Casper (dec'd) 1838  Stokes Taborn, Joel      1821  Granville Tack, Jacob      1832 Rutherford Tate, Thomas      1832  Orange Taylor, William    1832  Duplin Thomas, Jonathan    1820 Cumberland Thompson, Alexander   1824 Mecklenburg Thompson, John (dec'd)  1828 Mecklenburg Thorpe, Jonathan    1825  Stokes Tilley, John      1824  Rowan Tilley, Lazarus    1832  Orange Tilman, Phillip   1826  Lincoln Tipps, Jacob      1844  Burke Tolar, Daniel      1820  Craven Treadwell, Ruebin (dec'd)1832‐1834 Rutherford Truelove, John (dec'd) 1829 Perquimans Tucker, Robert     1827  Lincoln Turner, Charles    1834 Pasquotank Turner, James      1832ca Orange Turner, James (dec'd) 1839  Warren Tuttle, John (dec'd)  1849  Stokes Twiford, George    1828  Guilford Underwood, William    1824  Haywood Unger, Laurance    1844  Burke Vaughn, Stephen    1832  Wake Vendrick, Peter    1832  Craven Vinson, William (dec'd)  1851 Northampton Walker, Nathaniel    1821 New Hanover Wall, Joel      1845  Beaufort Wall, John      1832 New Hanover Wall, Richard      1825  Columbus                                     

Page 17: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                  Camin’s “Declarations of Service” List (cont.)  DEPONENT        DATE  COUNTY  Wallace, Thomas    1823  Burke Walling, Carhard    1818  Rowan Walton, Tilmon      1821  Burke Ward, Rachel (dec'd)  1845  Stokes Ward, William     1832  Sampson Warren, William    1821  Craven Waters, Moses      1832 Rutherford Watson, William    1833 Rutherford Weathers, Willis    1832 Rutherford Webb, James      1820 Cumberland‐Johnston Webb, Johnston      1832  Orange Wells, Jacob      1832 New Hanover Welsh, Theodocious (dec'd)1852Stokes West, William      1818  Rowan Wheeler, Benjamin    1820  Orange Whitaker, Robert L.    1832  Craven White, Benjamin    1832  Craven Whitehead, Burrel    1832  Wake Whiteburst, Anthony    1832 Pasquotank Whitt, Charles     1822  Lincoln Whitty, Micajah    1824  Nash Wilder, William    1832  Wake Wiley, (Rev.) Rufus    1832  Craven Williams, Jeremiah    1820 New Hanover Williams, John     1830 Rutherford Williams, William    1834 Rutherford Wilson, John (dec'd)  1834 Pasquotank Winninghan, James    1832  Randolph Wise, John      1820  Johnston Witherington, Solomon  1832  Craven Witherington, William  1832  Craven Withrow, James, Sr.    1832 Rutherford Witt, Charles      1804  Lincoln Wood, Cornelius    1819  Rowan Wood, Sampson      1832  Guilford Wood, William      1831 Cumberland 

Page 18: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Woosley, William    1824  Davidson Yeoman, John        1819 Cabarrus & Rowan Young, William (dec'd)  1844  Stokes Ziglar, Leonard (dec'd)  1832  Stokes                                      State Pensions to Invalids and Widows  In 1784, the General Assembly of North Carolina passed "An Act for the relief of such persons as have been disabled by wounds, or rendered incapable of procuring for themselves and families subsistence in the militia service of this State, and providing for the widows and orphans of such as have died". These pension papers listed below are located in the TREASURER'S AND COMPTROLLER'S PAPERS, Military Papers, Boxes 25‐30.  Alexander, William Allison, Andrew Anderson, David Balfour, Colonel Andrew ‐ heirs Bates, Isaac Baxter, John Beaty, John ‐ widow Leah Bennett, Nehemiah ‐ widow Sarah Relsiah, Thomas Bexley, Christopher Bradley, Joseph ‐ widow Ruth Buncombel Colonel Edward ‐ heirs Burkett, Moses Butler, Charles, Sr. Calleway, Richard Campbell, Daniel Campbell, Captain James ‐ Widow Isabella Camplin (Champlin), Jacob Carrigan, James Carter, Samuel Clark, Jesse Cole, Thomas Davidson, General William ‐ heirs Dennis, Alexander Dixon, Colonel Henry ‐ heirs, widow Martha 

Page 19: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Duckworth, John Ellams, Charles Elliott, Thomas Espey, Samuel Ewell, Thomas Field, William Flenniken, David Fort, Sherwood                                       State Pensions to Invalids and Widows (cont.)  Freeman, Samuel Gillon, John Gordon, Joshua Grissum, (Grisham), Richard Hall, William Harris, Burwell ‐ widow Elizabeth Harton, Howell Haynes, Alexander House, Elias Houston, Daniel Huddleston, John Hudson, Mary (later Mary Jones) Hulsey, Jesse Johnson, Samuel Johnston, Francis Kindrick, John Kennedy, Isaac Lamb, Colonel Gideon ‐ heirs Larimore, James McKissack, Thomas McLean, William Maynard, William Miller, David Miller, Matthew Minnis (Mines), John Moody, Thomas ‐ widow Mary Moore, General James ‐ heirs 

Page 20: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 Morgan, William ‐ widow Rachel Moreing, Christopher Morrison, Alexander ‐ widow Ann Morton Thomas Nash, Francis ‐ daughter Sarah Nelson, Jesse Parkinson, James ‐ heirs Parks, James Pittman, Matthew Porter, James Potts, James, Jr. Powell, Nathan Redfern, James                    State Pensions to Invalids and Widows (cont.)  Reep, Maichael Reaves, Elizabeth Reid, Isaac Rhem, Captain John Richardson, William Rigsby, Jesse Robertson, Jemina Rogers, Humphrey Seawell, Marv Shaw, Daniel ‐ widow Lucy Singletary, Joseph Spears, John Stanly, Hugh Starrett, John Taylor, Henry ‐ widow Mary Ann Thompson John ‐ widow Martha Truelove, Eleanor ‐ widow of John Warren, John ‐ widow Mary Wentz (Wence), John Wilfong, John Williams, Herbert ‐ widow Judah Wilson, James Wilson, William  ### 

Page 21: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                   

Page 22: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                                           Loyalist Records  The attached pages are part of a report of Loyalists' records located in the Archives by Dr. Robert Lambert, Department of History, Clemson University, as part of a national survey of similar materials in repositories throughout the country, conducted in 1970‐1971 by the Program for Loyalist Studies and Publications, under the sponsorship of the American Antiquarian Society, City University of New York, University of London, and University of New Brunswick, with headquarters at the Graduate Center, 33 West 42nd Street, New York, New York 10036.  PRIVATE COLLECTIONS Loyalist Materials  PC 123.10  James Cary Papers, 1777‐1805 (a part of the Thomas  

Pittman Papers). Letterbook, 1782‐1788, of Cary, South Carolina Loyalist planter and militia colonel; also loose letters, land papers, and other writing related to Cary’s claim for compensation from the Crown and to his travel and residence in Jamaica, Nova Scotia and England after the Revolution. 

 PC 40.1    Hayes Collection, 1748‐1806. Particularly in the correspondence of 

Samuel Johnston, Joseph Hewes, and others, 1775‐1776, is reflected their fears of the role which former Regulators might play if armed conflict broke out between Britain and her colonies. 

 PC 67.3  Correspondence of James Iredell, Sr., 1783‐1785, in Charles E. Johnston 

Collection. Concerns family matters primarily, but there are scattered references to efforts by Iredell and others to mitigate effects of the North Carolina confiscation laws on former loyalists. 

 PC 71.1  James Murray Papers, 1768‐1786. Typed copies (originals in 

Massachusetts Historical Society) of Letters of Murray, longtime North Carolina provincial office holder and resident, who moved to Boston and on its evacuation in 1776 to Halifax, Nova Scotia. Primarily family letters. 

                        

Page 23: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                                   Loyalist Records  PC 1097.1  Griffith Rutherford Miscellaneous. Letter of Rutherford to James Kerr, a 

Cape Fear Loyalist, July 2, 1783,refusing to help restore the latter’s property after the Revolution. Typed copy of original in A013, p. 113, Public Record Office, London.  

   PC 57.1  Fanning‐McCulloh Papers, 1752‐1786. Correspondence of Henry Eustace 

McCulloh and Edmund Fanning, former North Carolinians who left the province in the 1760’s. Primarily pre‐war with a few post‐war letters. 

 PC69.1; PC 196  Horatio Gates Letterbook, July 21, 1780‐October 7, 1781. There 

are scattered references to Tories in these microfilm copies and typescripts of originals in the new York Public Library. 

 PC 490.1  Edmund Fanning will made before he left for New York in 1775.  MISCELLANEOUS COLLECTION  

Series I. Volume, 1775‐1778, contains scattered references to Loyalists. Of marginal importance. 

        

Troop Returns: Box 2.1776: Tory Prisoners Commanded by Royal General Donald McDonald “in 

the Halifax Goal for Carrying arms in support of the Royal Authority.” April 4, 1776, after the battle of Moore’s Creek Bridge. Photostat. 

   War of the Revolution:   Box 4‐‐British and Loyalist Papers, 1776‐1783.  

Contains a “British Orderly Book, 1780‐1781.” Published in the North Carolina Historical Review, IX (1932).  [This British Orderly Book was found among the papers of William Hooper, a signer of the Declaration of Independence from North Carolina. It was given to Governor David L. Swain for the North Carolina Historical Society’s collection at the University of North Carolina by Hooper’s grandson, William Hooper, a faculty member at the University. Around 1868, Mrs. Swain removed some of  

                                    

Page 24: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                     Loyalist Records  

her late husband’s papers from the University. The Orderly Book was among those papers. It, along with  several other significant historical items, came to the North Carolina Historical Commission (now the NC Division of Historical Resources) through Judge Walter Clark, an executor of Mrs. Swain’s estate during biennium 1914‐1916.   Entries in the book begin on August 28, 1780. The Orderly Book appears to have belonged at a brigade under the command of Maj. Gen. Alexander Leslie, attached to General Clinton’s headquarters in New York. In October of 1780, the brigade was sent to Hampton Roads, Virginia. In November, the brigade was ordered by Lord Cornwallis to proceed to Charleston and then march to join him at Camden. Under Lord Cornwallis, General Leslie was given other duties, and the brigade was commanded by Brigadier General O’Hara. The brigade joined Lord Cornwallis several days after the battle of Cowpens and took part in what has become known as the “race to the Dan.” In March of 1781, the brigade took part in the battle of Guilford Court House. The last entry in the book was made in a camp near Deep River on March 20, 1781. 

The British orderly book was edited for publication by Dr. Albert Ray Newsome and is published with an introduction by Dr. Newsome in the North Carolina Historical Review, IX (1932), in four parts, Nos. 1,2,3 and 4.] 

 A transcript of “Observations of the War in Carolina” by Col. Robert Gray, paymaster of Loyalist militia in Charleston. Copied from original in Chalmers Mss., New York Public Library. 

 Discharge to Andrew Sickner in Nova Scotia, September 13, 1783, from Lt. Col. John Hamilton’s North Carolina Regiment. 

 Box 5‐‐Miscellaneous Papers, 1776‐1789. Deposition on recruiting of Loyalists in 

Wilkes County, Ga., by a Colonel Boyd, probably the same who was killed leading a party of Tories in the Battle of Kettle Creek, in Wilkes County, February 4, 1779. 

                   

Page 25: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                                        Loyalist Records  TREASURER’S AND COMPTROLLER’S PAPERS  

Land Estates, Boundaries and Surveys, 1760‐1801:  Boxes I‐VII—Confiscated Lands.  Receipts, plats, accounts, scattered correspondence. 

 Military papers:  Box I‐1776, Expenses of Jailing Tories; Box  

II—1777, Claims to Recover Expenses of Guarding Tories; Box III‐1778. Expenses of Jailing Tories. 

 ENGLISH RECORDS—Transcripts  

Box 12, folder 5‐‐Address to the King by Loyal American  Refugees, June, 1779‐‐109 signatures from Massachusetts and other provinces (from Public Record Office, Colonial Office Papers; America and West Indies—CO5). 

 Box 13, folders 15, 17‐‐letters from royal governors of  

Carolinas and Georgia,1777‐1782, containing numerous references to Loyalists; also photostatic copy of the North Carolina Confiscation  Act of December 12, 1777 (from CO5:178). 

   Box 13, folder 18‐‐Movements of Units in the Revolution, 1776— 

Letters from Clinton Expedition, 1776, against the Carolinas, includes a “narrative of the Proceeding of a Body of Loyalists in North Carolina” (Moore’s Creek Bridge campaign). (from CO5) 

   Box 13, folders 19, 20‐‐Correspondence from British officers  

in South Carolina on military movements in the Carolinas, 1780‐1781 (from CO5).    Box 13, folder 24‐‐correspondence in 1775‐1776 relating to the  

Clinton expedition which it was hoped would encourage the Loyalists (from CO5:184) 

   Box (?), folder 6 (guide says 8)‐‐Loyalists…Revolution— 

Page 26: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                

includes “State of Provincial Troops in South Carolina and Georgia under Sir Henry Clinton, March 8, 1780”; “List of Field Officers of the Established Provincial Corps of North America, 1781”; some letters of Maj. Gen., Lord Rawdon from South Carolina, 1781; and a “Form of Association for Loyalists in North Carolina.” (From CO5). 

                                     Loyalist Records  

Box 16, folder 1‐‐postwar petitions and memorials from North  Carolina Loyalists seeking favor from the British government, includes a photostatic copy of “The Summary Case of the American Loyalists” by agents of former Tories. (from Foreign Office Papers 4:1, Public Record Office). 

   Box 16, folder 14‐‐“Case of Capt. Wm. Lowe”—contains muster  

rolls and recruiting list of Duke of Cumberland’s Regiment which was recruited by Lord Charles Montagu (from Continental soldiers captured at the fall of Charles Town) for royal service in Jamaica, 1781. (Public Record Office, Home Office, State Papers, Domestic 41:29). 

 Box 16, folders 16‐20‐‐letters of transmittal and a few  

memorials of Loyalists seeking allowances from the Lords of the Treasury. (Public Record Office, Home Office Papers 36:1‐5). 

   Box 17, folders 9‐13—assorted Loyalist petitions, principally  

from North  Carolina. (Public Record Office, Treasury Papers, In‐letters, 1: 518, 520, 531,598, 622. 

 Box 17, folders 38‐44‐‐North Carolina Royal Militia pay  

records, quarterly pension lists (1794‐1831) documents relating to refugees, 1781‐1783. (Public Record Office, Treasury Papers; Miscellaneous, T50: 1‐3, 5, 28, 31‐40, 42, 44, 46‐48). 

   Box 18, folder 7‐‐Provincial Officers in the Revolution (N.C.  

Volunteers, N.C. Independent Co., N.C. Highland Regiment, N.C. Provincials). (Public Record Office, Treasury Papers; Miscellaneous, Various, T65:23). 

 Box 18, folder 12‐14‐‐Annual Army Lists—N.C. Provincial  

Page 27: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                

Officers, 1776‐1778 (for units above) (Public Record Office: War Office Papers, W028:4). 

                                                            Loyalist Records  SECRETARY OF STATE  

SS305‐‐local Committees of Safety, Journals, 1774‐1776, for  Tryon, Surry and Rowan Counties, New Bern District, and the Town of Wilmington contain references to “disaffected” persons. 

   SS306‐308‐‐Provincial Council of Safety, Minutes and  

Correspondence, 1775‐1776‐‐occasional references to the “disaffected,” especially in Box 306. 

   SS594‐‐Land Entry Books, Duplin County,1778‐1795, contain a  

few Loyalist entries.    SS700, 702, 703, 704, 705, 706‐‐Land Entry Books, Orange  

County, 1760‐1762‐‐strong Regulator country and many Regulators later stood for the King in the Revolution. 

   SS714‐‐Land Entries, Warrants and Surveys, Rowan County, 1778‐ 

1786, a county containing a number of Loyalists.  

SS760‐804‐‐Revolutionary Military Papers, 1767‐1855.  Applications for military land warrants based on military service on the American side. May be useful to identify those who served on both sides. 

   SS839‐87‐‐North Carolina Wills, 1663‐1789.    SS889‐905‐‐Inventories and Sales of Estates, 1733‐1798.  

Possibly useful to identify some Loyalists who remained in the State.  

Page 28: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                 COUNTY RECORDS    [If the searcher knows Loyalists by name, these records can be very valuable for him. He should have specific individuals in mind, however, or a good bit of time can be wasted here. Arrangement is generally alphabetical.]  Anson County    C.R.5 401.2‐3,5,8,13‐14,16‐16.1. Record of Deeds. See particularly Volumes III, IV, VII, b‐2, H, H‐I, K (parts 1,2).                                      Loyalist Records 

 C.R.5 801.1. Record of Wills. 

 Bertie County    L.P. 11.1, 46.1 (filed with Legislative Papers), Tax Lists,  

1784, 1781. C.R. 10.504.1. Estates Papers. 

  C.R. 10.702.1. Box 3, 1772‐1784. Taxables.  Bladen County    C.R. 11.0002‐3. Deeds, 1738‐1779, and Deeds and Grants, 1759‐ 

1804.  Brunswick County    L.P. 11.1; 64.1 (filed with Legislative Papers). Tax Lists,  

1772, 1784.   C.R. 12. 508. 1‐10. Estates Records  Burke County    C.R. 014.928.3. Miscellaneous Records, Revolutionary Papers,  

1777‐1783, contains names of enemies of the state and 128 names of persons whose property was confiscated for pro‐British activity. 

 Chatham County  

Page 29: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                   C.R. 022.301. 1‐2. County Court Minutes, 1774‐1779, 1781‐1785.   C.R. 022.801.1. Wills, 1782‐1794 (includes some inventories).  Chowan County  

C.R. 24.301.6‐8. Court of Pleas and Quarter Sessions, Minutes,  1772‐1787. 

C.R. 24.702.1. Taxables, most years, 1760‐1790. C.R. 24.801. 1‐4. Wills, 1674‐1808. 

   

              Loyalist Records  Craven County    C.R. 028.301.12‐13. County Court Minutes, 1776(?)‐1784. Part I  

contains proceedings in treason hearings by the state; Parts I and II contain matters relatedto confiscated property, 1778‐1784. 

 C.R. 028.928.13. State v. Jethro Oates (1780), trial for  

treason.  Cumberland County    C.R. 29.301.2‐4. County Court Minutes, 1772‐1787, contain  

references to persons who were banished for refusing to take the state oath. 

  C.R. 29.506.1‐83. Estates papers, 1759‐1888.   C.R. 29.701.1. List of Taxables, 1777‐1783. 

C.R. 29.801.1‐5. Record of Wills, 1757‐1869. (Microfilm copies) Record of Deeds and Grants, vols. II‐IX,  

1754‐1790; Deeds, vols. A‐C, 1764‐1796; Wills, vols. A‐C, 1764‐1954.  Duplin County    C.R. 035.514.1. Divisions of Estates, Inventories, 1757‐1804.   C.R. 035.801. 1‐12. Wills, 1759‐1913.  Guilford County  

Page 30: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                

C.R. 46.802.1. Wills, 1771‐1925. (Microfilm copies) Record of Deeds, vols.1‐3, 1771‐1784. 

 Mecklenburg County    C.R. 065.508.1‐124. Estates Record, 1735‐1902.   C.R. 065.801.1‐28. Record of Wills, 1749‐1869. 

C.R. 065.928. Miscellaneous Papers, especially for tax lists. (Microfilm copies) Record of Deeds, vols. 1‐19, 1762‐1826. 

 New Hanover County  

C.R. 070.508.1‐52. Estates Records, 1741‐1939.   C.R. 070.801.1‐5. Wills, 1732‐1864.                                      Loyalist Records  

(Microfilm copies) Deeds (and Wills), Vols. D‐H, 1760‐1788.  Orange County  

  C.R.073.401.1‐7. Deeds, 1755‐1927.   C.R.073.508.1‐95. Estates Records, 1771‐1911, and Equity Cases, 1764‐1867.   C.R.073.514.1. Inventories, Sales, and Accounts of Estates,  

1758‐1785.   C.R.073.801.1. Wills, 1753‐1819 and 1785‐1865.  Rowan County  

C.R.085.301.4. County Court Minutes, 1773‐1786. Several  significant lists of persons who refused to take the state oath or who failed to appear to defend their property against confiscation. 

  C.R.085.408.1. Estates Papers, 1753‐1920.   C.R.085.801.20. Wills, 1743‐1900. 

(Microfilm copies) Deeds, vols. 5‐11, 1762‐1800.  Rutherford County  

C.R.086.301.1‐2. County Court Minutes, 1779‐1786, 1781‐1786,  for occasional references to “enemies to the state.” 

C.R.086.401.1. Deeds, 1776‐1795. C.R.086.801.1. Wills, 1784‐1833. 

Page 31: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                  Surry County    L.P.11.1; 46.1 (filed under Legislative Papers), Tax Lists,  

1771‐1772, 1782.  Tryon County  

C.R.094.301.1‐2. County Court Minutes, 1769‐1774 (Part I); and  Tryon, 1774‐1779, and Lincoln Co., 1779‐1782 (Part II). 

  C.R.094.308.1. Trial, Reference and Appearance Docket, 1772‐ 1778 (primarily 1772‐1775). Many Loyalists’ names are here. 

                                          Loyalist Records  DISTRICT COURT RECORDS  

  D.S.C.R.204.321.2. Hillsborough District, Superior Court,  Miscellaneous Records—includes folder on confiscated property, 1786, 1788, and 1793. 

 

  D.S.C.R.206.928.2. New Bern District, Superior Court,  Miscellaneous Records, Boxes A‐J. Among them is the famous case of Bayard v. Singleton (1786) and the related case of Cornell v. Singleton (1786). 

 D.S.C.R.4.008. Salisbury District, Superior Court Minutes,  

1778‐1779. Some evidence of conspiracies to join the King are here.  

  D.S.C.R.207.324.11‐12. Superior Court, Salisbury District,  Minutes; Miscellaneous Papers, 1781‐1782—(1) Civil and criminal cases, 1781—depositions about Tory activity; (2) Civil and Criminal Cases, 1782—indictments and testimony in treason trials. 

                 

Page 32: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                  GOVERNOR”S LETTERBOOKS  

G.L.B.1.1‐5. 1777‐1785. Scattered references to Tory activity  are to be found in these five volumes. 

                    For other materials on the War of the Revolution see:  1. TREASURER’S AND COMPTROLLER’S PAPERS, Military Papers. TREASURER’S AND COMPTROLLER’S PAPERS, Lands, Estates, Boundaries, and Surveys; Confiscated Lands. Detailed checklist located in the finding media. 

 2. SECRETARY OF STATE’S OFFICE   Box 305. Committees of Safety   Box 307. Council of Safety 

Box 308. Council of Safety Journal, 1776   Box 759. Land entries of the Continental Line, 1783 

Box 760‐804.1. Revolutionary Military Papers, 1776‐1855     (alphabetical index located in card catalogue)   Box 912. Wilmington‐New Hanover Committee of Safety                                        Box 913. Pitt County Committee of Safety   Box 913‐A. Pitt County Committee of Safety   Box 979. Continental Line land Warrants, Part I   Box 980. Continental Line land Warrants, Part II 

Box 981. Continental Line land Warrants, Part III   Box 981.1. Military Land Warrant Book, 1783‐1841  3. GOVERNOR’S PAPERS   Richard Caswell, 1776‐1780; 1784‐1787   Abner Nash, 1780‐1781   Thomas Burke, 1781‐1782   Alexander Martin, 1782‐1784; 1789‐1792         Index to the above papers located in the card catalogue.  4. LEGISLATIVE PAPERS 

Index to the above papers located in the card catalog.  5. Private Collections 

Page 33: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                

ABISHAI THOMAS PAPERS LIDA T. RODMAN COLLECTION DARTMOUTH MANUSCRIPTS JOSEPH GRAHAM PAPERS MISCELLANEOUS PAPERS, VOL. I RICHARD CASWELL PAPERS WILLIAM CASWELL PAPERS SAMUEL JOHNSTON PAPERS JACOB TURNER DIARY EUROPEAN MANUSCRIPTS RELATING TO AMERICA, 1773‐1783 THOMAS ADDISON EMMET COLLECTION JOHN GRAY BLOUNT PAPERS RICHARD COGDELL PAPERS DICKSON MANUSCRIPTS ENGLISH RECORDS DAVID FANNING PAPERS HAYES COLLECTION WILLIAM RICHARDSON DAVIE PAPERS ALEXANDER BREVARD PAPERS JETHRO SUMNER PAPERS WILLIAM ALEXANDER GRAHAM PAPERS HUGH WILLIAMSON PAPERS CONTINENTAL CONGRESS DELEGATES’ PAPERS FARLIN Q. BALL COLLECTION HISTORICAL SOCIETY OF PENNSYLVANIA PAPERS JOHN ALEXANDER ROBESON PAPERS 

                                    

 6. Printed materials in the Search Room 

The State and Colonial Records of North Carolina Historical Register of Officers of the Continental Army, April  

1775‐December 1783 “Roster of Soldiers from North Carolina in the American  

Revolution” “List of Soldiers of North Carolina in the American  

Revolution” “General Joseph Graham and His Revolutionary Papers” “The Loyalists in North Carolina During the Revolution” “Index to Revolutionary War Pension Applications in the  

National Archives” 

Page 34: MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No ...MILITARY COLLECTION V. WAR OF THE REVOLUTION Box No. Contents 1 Board of War, 1780‐1781 Account of John Haywood, secretary

MILITARY COLLECTION               V. WAR OF THE REVOLUTION 

                

“North Carolina Troops in the Continental Line and North  Carolina Pension Roll” 

“Revolutionary Claims and Pensions, 1829‐1831, and Recently  Discovered Records Relating to Revolutionary War Veterans Who Applied for Pensions Under the Act of 1792” 

“Census of Pensioners for Revolutionary or Military Services,  1840” 

“Seventeenth Report of the National Society of Daughters of  the American Revolution, 1913‐1914” 

“Lineage Book of the North Carolina Society of Sons of the  American Revolution” 

 7. National Archives records on microfilm 

 Index to Compiled Service Records of Volunteer Soldiers Who  

Served during the Revolutionary War from North Carolina